-
THE GREEDY GOOSE LIMITED - The Coach House, Cradley, Malvern, WR13 5LQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07445826
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Coach House
- Cradley
- Malvern
- WR13 5LQ
- England The Coach House, Cradley, Malvern, WR13 5LQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HARWOOD, Andrew Ossie
- WILLMOTT, John Martin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-22 13 Jahre
- SIC/NACE
- 56302
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Martin Willmott
- -
- Mr Andrew Ossie Harwood
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-15
- Letzte Einreichung: 2020-12-01
-
THE GREEDY GOOSE LIMITED Firmenbeschreibung
- THE GREEDY GOOSE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07445826. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.11.2012.Die Firma kann schriftlich über The Coach House erreicht werden.
Jetzt sichern THE GREEDY GOOSE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Greedy Goose Limited - The Coach House, Cradley, Malvern, WR13 5LQ, Grossbritannien
- 2010-11-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE GREEDY GOOSE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-15) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-04) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-04) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-16) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-06) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-26) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-10) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-05) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-13) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2013-02-18) - RP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-02-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-08-13) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2012-08-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-21) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-22) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-11-25) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-11-22) - TM01
-
incorporation-company (2010-11-22) - NEWINC