-
CHASE WINDOW COMPANY HOLDINGS LIMITED - Suite I Windrush Court, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07445537
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite I Windrush Court
- Abingdon Business Park
- Abingdon
- Oxfordshire
- OX14 1SY
- United Kingdom Suite I Windrush Court, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1SY, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- WOODHATCH, Gary
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-19 13 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Joanne Woodhatch
- Mr Gary Woodhatch
- -
- -
- Artemas Joseph Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-13
- Letzte Einreichung: 2021-02-27
-
CHASE WINDOW COMPANY HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- CHASE WINDOW COMPANY HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07445537. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite I Windrush Court erreicht werden.
Jetzt sichern CHASE WINDOW COMPANY HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Chase Window Company Holdings Limited - Suite I Windrush Court, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire, Grossbritannien
- 2010-11-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHASE WINDOW COMPANY HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-03-01) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-01) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-08) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-07-10) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-27) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-28) - PSC02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-09-17) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-17) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-27) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-12-04) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-10-05) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-03) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-10-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-09) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-20) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-04-20) - PSC09
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-04-29) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-27) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-22) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2015-03-24) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-07) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-02-16) - AA01
-
capital-allotment-shares (2011-01-17) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-01-10) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-11-19) - TM01
-
incorporation-company (2010-11-19) - NEWINC