-
REJOICE HOMES LTD - 364 - 366 Cemetery Road, Sheffield, S11 8FT, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07441643
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 364 - 366 Cemetery Road
- Sheffield
- S11 8FT
- England 364 - 366 Cemetery Road, Sheffield, S11 8FT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-16 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Sheng Shyan Ling
- Mr Kah Seen Stephen Ng
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- WAKECO (424) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-07-31
- Letzte Einreichung: 2022-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-05
- Letzte Einreichung: 2023-08-22
-
REJOICE HOMES LTD Firmenbeschreibung
- REJOICE HOMES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07441643. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.11.2010 registriert. REJOICE HOMES LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WAKECO (424) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 364 - 366 Cemetery Road erreicht werden.
Jetzt sichern REJOICE HOMES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rejoice Homes Ltd - 364 - 366 Cemetery Road, Sheffield, S11 8FT, England, Grossbritannien
- 2010-11-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REJOICE HOMES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-05-24) - DS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-22) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-22) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-22) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-27) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-25) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-02-06) - DISS40
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-03) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2016-02-02) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-07-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-08-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-12) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-04-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-19) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-01-11) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-01-11) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-01-11) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-01-13) - CH01
-
certificate-change-of-name-company (2011-01-07) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-01-07) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-18) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-01-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-16) - NEWINC