-
THE PRINCIPLE TRUST CHILDREN'S CHARITY LTD - Airedale Business Centre, Millenium Road, Skipton, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07440015
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Airedale Business Centre
- Millenium Road
- Skipton
- North Yorkshire
- BD23 2TZ Airedale Business Centre, Millenium Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2TZ UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMPBELL, Clare
- DAVIES, Andrew Michael
- DAVIES, Michael John
- HARDING, Ann
- THOMAS, Simon Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc
- Gründungsdatum
- 15.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Clare Campbell
- Miss Clare Campbell
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- THE PRINCIPLE TRUST LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-29
- Letzte Einreichung: 2020-11-15
-
THE PRINCIPLE TRUST CHILDREN'S CHARITY LTD Firmenbeschreibung
- THE PRINCIPLE TRUST CHILDREN'S CHARITY LTD ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc registrierte Firma mit der Register-Nr. 07440015. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.11.2010 registriert. THE PRINCIPLE TRUST CHILDREN'S CHARITY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THE PRINCIPLE TRUST LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Airedale Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern THE PRINCIPLE TRUST CHILDREN'S CHARITY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Principle Trust Children's Charity Ltd - Airedale Business Centre, Millenium Road, Skipton, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2010-11-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE PRINCIPLE TRUST CHILDREN'S CHARITY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-21) - AP01
-
change-of-name-notice (2020-08-16) - CONNOT
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-15) - CS01
-
resolution (2020-08-16) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-08) - AA
-
change-of-name-request-comments (2020-08-16) - NM06
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-18) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-25) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-13) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-02) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-21) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-of-name-request-comments (2016-08-02) - NM06
-
change-of-name-notice (2016-08-02) - CONNOT
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-06-10) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-01-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-11-23) - AR01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-01-13) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-01-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2014-11-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-11-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2013-01-09) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2013-11-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-08-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-07-25) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2012-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-15) - NEWINC