-
PHOENIX TRAINING & TECHNOLOGIES LIMITED - White House, Wollaton Street, Nottingham, NG1 5GF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07438135
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- White House
- Wollaton Street
- Nottingham
- NG1 5GF White House, Wollaton Street, Nottingham, NG1 5GF UK
Management
- Geschäftsführung
- SMITH, Gavin Strafford
- WINFIELD, Simon Jon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-12 13 Jahre
- SIC/NACE
- 85590
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Phoenix Technology Group Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CEREBUS TRAINING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-26
- Letzte Einreichung: 2022-11-12
-
PHOENIX TRAINING & TECHNOLOGIES LIMITED Firmenbeschreibung
- PHOENIX TRAINING & TECHNOLOGIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07438135. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.11.2010 registriert. PHOENIX TRAINING & TECHNOLOGIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CEREBUS TRAINING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85590" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/11/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.11.2012.Die Firma kann schriftlich über White House erreicht werden.
Jetzt sichern PHOENIX TRAINING & TECHNOLOGIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Phoenix Training & Technologies Limited - White House, Wollaton Street, Nottingham, NG1 5GF, Grossbritannien
- 2010-11-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PHOENIX TRAINING & TECHNOLOGIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-03-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-02-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-30) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-30) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-30) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-03-16) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-02-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-03-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-09) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-06) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-05-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-15) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-12) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-03) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-01-13) - RP04
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-01) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-03-12) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-06) - AA
-
resolution (2013-06-25) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-04) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-09-05) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2012-01-20) - CERTNM
-
resolution (2012-01-12) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-12-28) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2011-12-28) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-12) - NEWINC