-
ASSURED CARE (NORTH WEST) LIMITED - Consort House 1st Floor, Waterdale, Doncaster, DN1 3HR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07435939
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Consort House 1st Floor
- Waterdale
- Doncaster
- DN1 3HR Consort House 1st Floor, Waterdale, Doncaster, DN1 3HR UK
Management
- Geschäftsführung
- CAUNCE, Brian Henry
- HUMPHREYS, Lisa
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.11.2010
- Gelöscht am:
- 2020-03-19
- SIC/NACE
- 87900
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-12-31
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-10
-
ASSURED CARE (NORTH WEST) LIMITED Firmenbeschreibung
- ASSURED CARE (NORTH WEST) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07435939. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Consort House 1St Floor erreicht werden.
Jetzt sichern ASSURED CARE (NORTH WEST) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Assured Care (North West) Limited - Consort House 1st Floor, Waterdale, Doncaster, DN1 3HR, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ASSURED CARE (NORTH WEST) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-03-19) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-12-19) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-09-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-07-21) - 600
-
resolution (2016-07-21) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-07-21) - 4.20
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-19) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-10) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-02-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-08-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-05-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-01-07) - TM01
-
capital-allotment-shares (2011-01-07) - SH01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-10) - NEWINC