-
ASHLEY AND PHOEBE LIMITED - Kingston House, Northampton Road, Newport Pagnell, Buckingham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07419954
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Kingston House
- Northampton Road
- Newport Pagnell
- Buckingham
- MK16 8NJ Kingston House, Northampton Road, Newport Pagnell, Buckingham, MK16 8NJ UK
Management
- Geschäftsführung
- THOMPSON, Jessica
- THOMPSON, Lucy Kate
- THOMPSON, Michael Anthony Norcott
- THOMPSON, Sophie Kate
- THOMPSON, William Henry
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.10.2010
- Alter der Firma 2010-10-27 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Lucy Kate Thompson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-07-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-30
- Letzte Einreichung: 2020-10-16
-
ASHLEY AND PHOEBE LIMITED Firmenbeschreibung
- ASHLEY AND PHOEBE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07419954. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.10.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Kingston House erreicht werden.
Jetzt sichern ASHLEY AND PHOEBE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ashley And Phoebe Limited - Kingston House, Northampton Road, Newport Pagnell, Buckingham, Grossbritannien
- 2010-10-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ASHLEY AND PHOEBE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-08-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-06) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-02-03) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-08) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-01-08) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-08) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-16) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-11) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-05) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-17) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-30) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-03) - AR01
-
resolution (2015-11-10) - RESOLUTIONS
-
mortgage-acquire-with-deed-with-charge-number-charge-acquisition-date (2015-11-12) - MR02
-
legacy (2015-11-12) - MG06
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-18) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-12) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-12-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-26) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-30) - AR01
-
move-registers-to-registered-office-company (2012-10-30) - AD04
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-23) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-11-23) - CH01
-
move-registers-to-sail-company (2011-11-23) - AD03
-
change-sail-address-company (2011-11-23) - AD02
-
legacy (2011-02-24) - MG01
-
legacy (2011-02-17) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-secretary-company-with-name (2010-10-28) - TM02
-
incorporation-company (2010-10-27) - NEWINC