-
ALLYOUNG LIMITED - 11 Radford Crescent, Billericay, Essex, CM12 0DW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07412528
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Radford Crescent
- Billericay
- Essex
- CM12 0DW 11 Radford Crescent, Billericay, Essex, CM12 0DW UK
Management
- Geschäftsführung
- MITCHELL, Sally
- YOUNG, John Richard
- DRUMGOLD, Lindsey Patricia
- MITCHELL, Gavin William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.10.2010
- Alter der Firma 2010-10-19 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Richard Young
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-02
- Letzte Einreichung: 2021-05-19
-
ALLYOUNG LIMITED Firmenbeschreibung
- ALLYOUNG LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07412528. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.10.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 11 Radford Crescent erreicht werden.
Jetzt sichern ALLYOUNG LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Allyoung Limited - 11 Radford Crescent, Billericay, Essex, CM12 0DW, Grossbritannien
- 2010-10-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALLYOUNG LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-24) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-09) - AA
-
legacy (2020-05-27) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-05-27) - SH19
-
legacy (2020-05-27) - CAP-SS
-
resolution (2020-05-27) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-05-21) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-31) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-19) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-06-18) - SH08
-
memorandum-articles (2020-06-09) - MA
-
resolution (2020-06-09) - RESOLUTIONS
-
resolution (2020-05-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-24) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-23) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-18) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-28) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-09) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-24) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-12) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-01) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-01) - PSC01
-
capital-allotment-shares (2017-08-11) - SH01
-
memorandum-articles (2017-01-08) - MA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-10-04) - AA
-
resolution (2015-04-10) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-10-02) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-01-14) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-29) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-09) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-07-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-04-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-10-19) - NEWINC