-
BRIDGEBROOKE ENERGY LIMITED - COFFIN MEW LLP, 1000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07401302
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- COFFIN MEW LLP
- 1000 Lakeside Western Road
- Portsmouth
- Hampshire
- PO6 3EN COFFIN MEW LLP, 1000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Hampshire, PO6 3EN UK
Management
- Geschäftsführung
- MILNE, Alan Graham
- Prokuristen
- MILNE, Alan Graham
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.10.2010
- Alter der Firma 2010-10-08 13 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Bsw Energy Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GREEN BRIDGE ENERGY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-08
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-22
- Letzte Einreichung: 2023-10-08
-
BRIDGEBROOKE ENERGY LIMITED Firmenbeschreibung
- BRIDGEBROOKE ENERGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07401302. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.10.2010 registriert. BRIDGEBROOKE ENERGY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GREEN BRIDGE ENERGY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 08.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Coffin Mew Llp erreicht werden.
Jetzt sichern BRIDGEBROOKE ENERGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bridgebrooke Energy Limited - COFFIN MEW LLP, 1000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Hampshire, Grossbritannien
- 2010-10-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRIDGEBROOKE ENERGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
legacy (2023-10-23) - AGREEMENT2
-
resolution (2023-11-29) - RESOLUTIONS
-
legacy (2023-11-29) - SH20
-
legacy (2023-11-29) - CAP-SS
-
capital-allotment-shares (2023-11-29) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-10-23) - AA
-
legacy (2023-10-23) - GUARANTEE2
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2023-11-29) - SH19
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-09-01) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-09-15) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-20) - AA
-
legacy (2022-08-08) - AGREEMENT2
-
legacy (2022-08-08) - GUARANTEE2
-
change-account-reference-date-company (2022-01-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-02-05) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-04) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-10) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-26) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-06) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-02-21) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-08-19) - AA01
-
resolution (2020-02-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-06) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-06) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-06) - PSC07
-
legacy (2019-05-29) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-05-17) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-03) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-01-22) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-09) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-11) - PSC05
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-30) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-05) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-23) - MR04
-
change-account-reference-date-company (2015-01-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-12-10) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-12-10) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-10) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-25) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-09-05) - AA01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-10-31) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-10) - AA
-
legacy (2012-02-01) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-11-16) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2010-10-15) - CERTNM
-
incorporation-company (2010-10-08) - NEWINC