-
LOUTH CARE LIMITED - Suite 4 164-170 Queens Road, Sheffield, S2 4DH, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07391203
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 4 164-170 Queens Road
- Sheffield
- S2 4DH
- England Suite 4 164-170 Queens Road, Sheffield, S2 4DH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BULLAS, Michael Neville
- Prokuristen
- BUSINESS ACTION LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-29 13 Jahre
- SIC/NACE
- 87100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Hlwch 900 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-13
- Letzte Einreichung: 2020-09-29
-
LOUTH CARE LIMITED Firmenbeschreibung
- LOUTH CARE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07391203. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite 4 164-170 Queens Road erreicht werden.
Jetzt sichern LOUTH CARE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Louth Care Limited - Suite 4 164-170 Queens Road, Sheffield, S2 4DH, England, Grossbritannien
- 2010-09-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LOUTH CARE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2021-05-07) - RP04CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-07-02) - AA
-
capital-allotment-shares (2021-05-06) - SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-10) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-29) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-03-21) - RESOLUTIONS
-
legacy (2018-03-21) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-03-21) - SH19
-
legacy (2018-03-21) - SH20
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-01) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-11-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-07) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-07-29) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-25) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-03) - MR01
-
resolution (2014-01-23) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-22) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-08) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-01-23) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-01-23) - SH02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-22) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-01-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-28) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-06-25) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-29) - AA
-
legacy (2012-04-27) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-10-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-09-29) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-26) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2010-10-20) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name (2010-10-04) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-10-04) - TM01