-
CAU RESTAURANTS LIMITED - Four Brindleyplace, Birmingham, B1 2HZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07381319
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Four Brindleyplace
- Birmingham
- B1 2HZ Four Brindleyplace, Birmingham, B1 2HZ UK
Management
- Geschäftsführung
- BANDURA, Frank
- MASON, Paul
- MEAKIN, Oliver James
- Prokuristen
- BANDURA, Frank
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.09.2010
- Gelöscht am:
- 2019-10-31
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Gaucho Grill Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-20
-
CAU RESTAURANTS LIMITED Firmenbeschreibung
- CAU RESTAURANTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07381319. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Four Brindleyplace erreicht werden.
Jetzt sichern CAU RESTAURANTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cau Restaurants Limited - Four Brindleyplace, Birmingham, B1 2HZ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAU RESTAURANTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
bona-vacantia-company (2021-05-14) - BONA
keyboard_arrow_right 2020
-
bona-vacantia-company (2020-08-28) - BONA
keyboard_arrow_right 2019
-
bona-vacantia-company (2019-12-10) - BONA
-
bona-vacantia-company (2019-12-03) - BONA
-
bona-vacantia-company (2019-11-28) - BONA
-
gazette-dissolved-liquidation (2019-10-31) - GAZ2
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2019-07-31) - AM23
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-03-03) - AM10
-
bona-vacantia-company (2019-12-13) - BONA
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-07-04) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2018-07-04) - MA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-03) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-29) - AP01
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2018-09-12) - AM02
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-09-16) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2018-10-01) - AM06
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-09-12) - AM01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-08) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-08) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-08) - AP01
-
second-filing-of-secretary-termination-with-name (2017-04-03) - RP04TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-10) - TM01
-
second-filing-of-director-termination-with-name (2017-04-03) - RP04TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-18) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-28) - MR01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-08-12) - RP04
-
resolution (2014-05-23) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-11-11) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-11-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-11-11) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-05-10) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-06-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-11-14) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-22) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-22) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-09-22) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2010-09-21) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-09-21) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-09-21) - TM02
-
incorporation-company (2010-09-20) - NEWINC