-
JOSHUA PROPERTIES LIMITED - 1st & 2nd Floors 61 Curzon Street, London, W1J 8PD, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07379906
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st & 2nd Floors 61 Curzon Street
- London
- W1J 8PD
- United Kingdom 1st & 2nd Floors 61 Curzon Street, London, W1J 8PD, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- GATLEY, John Andrew
- GOURGEY, Charles Richard
- YOUNG, Craig Robert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-17 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mclaren Property Holdings Llp
- Eliterank Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-11
- Letzte Einreichung: 2023-06-27
-
JOSHUA PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- JOSHUA PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07379906. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1St & 2Nd Floors 61 Curzon Street erreicht werden.
Jetzt sichern JOSHUA PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Joshua Properties Limited - 1st & 2nd Floors 61 Curzon Street, London, W1J 8PD, United Kingdom, Grossbritannien
- 2010-09-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JOSHUA PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-person-director-company-with-change-date (2024-01-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-01-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-06-19) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-06-19) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-26) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-07-04) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-03) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-03-15) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-01-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-05-11) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-28) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-06) - AR01
-
auditors-resignation-company (2015-11-23) - AUD
keyboard_arrow_right 2014
-
auditors-resignation-company (2014-09-26) - AUD
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-04-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-13) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-09) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-28) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-05-03) - AA
-
miscellaneous (2012-10-08) - MISC
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-01-23) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-18) - AR01
-
legacy (2011-10-06) - MG01
-
capital-allotment-shares (2011-02-01) - SH01
-
legacy (2011-01-11) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-16) - AP01
-
capital-allotment-shares (2010-12-20) - SH01
-
incorporation-company (2010-09-17) - NEWINC
-
capital-name-of-class-of-shares (2010-12-20) - SH08