-
PROJECT SUPPORT CONSULTANTS LTD - 12 Castle View, Barrow In Furness, Cumbria, LA14 3YB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07376483
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 12 Castle View
- Barrow In Furness
- Cumbria
- LA14 3YB 12 Castle View, Barrow In Furness, Cumbria, LA14 3YB UK
Management
- Geschäftsführung
- HIGHAM, Roger
- Prokuristen
- HIGHAM, Jennifer Anne
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Roger Higham
- Mrs Jennifer Anne Higham
- Mr Roger Higham
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-29
- Letzte Einreichung: 2021-09-15
-
PROJECT SUPPORT CONSULTANTS LTD Firmenbeschreibung
- PROJECT SUPPORT CONSULTANTS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07376483. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 12 Castle View erreicht werden.
Jetzt sichern PROJECT SUPPORT CONSULTANTS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Project Support Consultants Ltd - 12 Castle View, Barrow In Furness, Cumbria, LA14 3YB, Grossbritannien
- 2010-09-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PROJECT SUPPORT CONSULTANTS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-12-21) - DS01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-09-17) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-11-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-12-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-18) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-01-10) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-01) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-10) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-10-31) - SH08
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-15) - AR01
-
resolution (2014-10-31) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-05) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-03) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-03-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-11) - CH01
-
capital-allotment-shares (2010-10-07) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-29) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-09-29) - AP03
-
incorporation-company (2010-09-15) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2010-09-20) - TM01