-
FAIRLIE PROPERTIES LIMITED - C/O Bishop Fleming Llp, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07372402
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Bishop Fleming Llp
- 10 Temple Back
- Bristol
- BS1 6FL
- United Kingdom C/O Bishop Fleming Llp, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- WHELAN, John Gregory
- MCGRANAGHAN, Terence Patrick
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-10 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Fairlie Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-24
- Letzte Einreichung: 2022-09-10
-
FAIRLIE PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- FAIRLIE PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07372402. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.09.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Bishop Fleming Llp erreicht werden.
Jetzt sichern FAIRLIE PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fairlie Properties Limited - C/O Bishop Fleming Llp, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, Grossbritannien
- 2010-09-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FAIRLIE PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-03-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-05) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-02-23) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-02-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-05-06) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-08-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-09-28) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-06-26) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-04-04) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-20) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-24) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-12-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-25) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-11-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-17) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-04-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-01-02) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-01-07) - MR04
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-28) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-05-26) - MG01
-
legacy (2011-04-23) - MG01
-
legacy (2011-03-09) - MG01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-03-08) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-23) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-02-23) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-03) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-09-10) - NEWINC