-
MEAKIN ENTERPRISES LIMITED - Unit 1 Raymond Street, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST1 4DP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07369424
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 1 Raymond Street
- Stoke-On-Trent
- Staffordshire
- ST1 4DP
- England Unit 1 Raymond Street, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST1 4DP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ASCOTT-MEAKIN, Deborah Rachael Elizabeth
- MEAKIN, Michael Donald
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.09.2010
- Gelöscht am:
- 2020-10-27
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Deborah Ascott-Meakin
- Mr Michael Donald Meakin
- Mrs Deborah Ascott-Meakin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SAMUI BEACH VILLAGE PROPERTIES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2020-05-11
-
MEAKIN ENTERPRISES LIMITED Firmenbeschreibung
- MEAKIN ENTERPRISES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07369424. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.09.2010 registriert. MEAKIN ENTERPRISES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SAMUI BEACH VILLAGE PROPERTIES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 11.05.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 1 Raymond Street erreicht werden.
Jetzt sichern MEAKIN ENTERPRISES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Meakin Enterprises Limited - Unit 1 Raymond Street, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST1 4DP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MEAKIN ENTERPRISES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-10-27) - GAZ2(A)
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-03) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-04) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-05-11) - AA01
-
gazette-notice-voluntary (2020-08-11) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-07-30) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-14) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-09-14) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-14) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-08) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-09-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-15) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-02-27) - SH01
-
memorandum-articles (2015-02-27) - MA
-
resolution (2015-02-27) - RESOLUTIONS
-
statement-of-companys-objects (2015-02-27) - CC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-13) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-01-08) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-01-08) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-14) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-15) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-09-27) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-02-08) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-02-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-09-08) - NEWINC