-
EPSL LIMITED - Old Library Chambers, 21 Chipper Lane, Salisbury, Wiltshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07367527
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Old Library Chambers
- 21 Chipper Lane
- Salisbury
- Wiltshire
- SP1 1BG Old Library Chambers, 21 Chipper Lane, Salisbury, Wiltshire, SP1 1BG UK
Management
- Geschäftsführung
- WARR, Nicholas David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-07 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Hrh Prince Salman Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud
- Hrh Prince Salman Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- 75 EATON PLACE SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-09-30
- Letzte Einreichung: 2023-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-21
- Letzte Einreichung: 2023-09-07
-
EPSL LIMITED Firmenbeschreibung
- EPSL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07367527. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.09.2010 registriert. EPSL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 75 EATON PLACE SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Old Library Chambers erreicht werden.
Jetzt sichern EPSL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Epsl Limited - Old Library Chambers, 21 Chipper Lane, Salisbury, Wiltshire, Grossbritannien
- 2010-09-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EPSL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-05-17) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-15) - CS01
-
resolution (2021-04-15) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-07) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-20) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-22) - AA
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-05) - PSC09
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-26) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-31) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-29) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-05) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-02-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-05-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-02-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-05-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-05-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-27) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-05-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-12) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-09-13) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-09-13) - TM01
-
incorporation-company (2010-09-07) - NEWINC