-
MASONS ARMS (LOUTH) LIMITED - Glanford House, Bridge Street, Brigg, DN20 8NF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07364794
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Glanford House
- Bridge Street
- Brigg
- DN20 8NF
- England Glanford House, Bridge Street, Brigg, DN20 8NF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWN, Joanne
- NICKERSON, Charles Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-03 14 Jahre
- SIC/NACE
- 56302
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mrs Joanne Brown
- Mr Charles Joseph Nickerson
- -
- Mrs Joanne Brown
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- YAFFLE INVESTMENTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-07-22
- Letzte Einreichung: 2022-07-08
-
MASONS ARMS (LOUTH) LIMITED Firmenbeschreibung
- MASONS ARMS (LOUTH) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07364794. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.09.2010 registriert. MASONS ARMS (LOUTH) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen YAFFLE INVESTMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Glanford House erreicht werden.
Jetzt sichern MASONS ARMS (LOUTH) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Masons Arms (Louth) Limited - Glanford House, Bridge Street, Brigg, DN20 8NF, Grossbritannien
- 2010-09-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MASONS ARMS (LOUTH) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-19) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-07-19) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-07-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-30) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-09-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-17) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-17) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-17) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-18) - MR01
-
resolution (2017-04-13) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-11) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-10) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-04-13) - SH08
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-04) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-04) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-04-13) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-09) - TM01
-
resolution (2016-11-07) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-17) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-13) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-06) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-09-03) - NEWINC