-
NEW VISION SIGNS & GRAPHICS LIMITED - 6 Ventnor Street, Bradford, BD3 9JP, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07354344
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6 Ventnor Street
- Bradford
- BD3 9JP
- England 6 Ventnor Street, Bradford, BD3 9JP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ROBERTS, Garry Stephen
- Prokuristen
- ROBERTS, Zoe
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.08.2010
- Alter der Firma 2010-08-24 13 Jahre
- SIC/NACE
- 18129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Strebor Signs Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- NEW VISIONS SIGNS & GRAPHICS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-07
- Letzte Einreichung: 2022-08-24
-
NEW VISION SIGNS & GRAPHICS LIMITED Firmenbeschreibung
- NEW VISION SIGNS & GRAPHICS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07354344. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.08.2010 registriert. NEW VISION SIGNS & GRAPHICS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEW VISIONS SIGNS & GRAPHICS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "18129" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 6 Ventnor Street erreicht werden.
Jetzt sichern NEW VISION SIGNS & GRAPHICS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: New Vision Signs & Graphics Limited - 6 Ventnor Street, Bradford, BD3 9JP, England, Grossbritannien
- 2010-08-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEW VISION SIGNS & GRAPHICS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-06-01) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-06-01) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-06-01) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-24) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-31) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-10-25) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-10-25) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-06) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2022-03-17) - CH03
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2022-03-16) - CH03
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-25) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-24) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-24) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-19) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-02) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-08-24) - TM01
-
legacy (2010-10-05) - MG01
-
capital-allotment-shares (2010-10-04) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-09-27) - AP03
-
resolution (2010-09-06) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-31) - AP01
-
incorporation-company (2010-08-24) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2010-09-06) - CERTNM