-
RHENUS TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED - Keiler House, Challenge Road, Ashford, Middlesex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07346069
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Keiler House
- Challenge Road
- Ashford
- Middlesex
- TW15 1AX Keiler House, Challenge Road, Ashford, Middlesex, TW15 1AX UK
Management
- Geschäftsführung
- BRAUNE, Carsten
- KENNERLEY, Richard
- Prokuristen
- KENNERLEY, Richard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.08.2010
- Gelöscht am:
- 2020-10-13
- SIC/NACE
- 71200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Rhenus High Tech Uk Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- LUPPRIAN'S TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-27
- Letzte Einreichung: 2019-08-16
-
RHENUS TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- RHENUS TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07346069. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.08.2010 registriert. RHENUS TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LUPPRIAN'S TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Keiler House erreicht werden.
Jetzt sichern RHENUS TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rhenus Technical Solutions Limited - Keiler House, Challenge Road, Ashford, Middlesex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RHENUS TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-07-28) - GAZ1(A)
-
legacy (2020-02-05) - CAP-SS
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-07-16) - DS01
-
legacy (2020-02-05) - SH20
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-08-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-06) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-06) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-06) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-05-11) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-14) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-03-14) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-04-27) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2015-02-25) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-12-01) - TM02
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-12-23) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-01) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-11-05) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-27) - AR01
-
auditors-resignation-company (2013-08-19) - AUD
-
auditors-resignation-company (2013-07-29) - AUD
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-07-13) - MR04
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-08-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-24) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-04-13) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2012-04-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-07-21) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-07-22) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-11-02) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-18) - AP01
-
legacy (2010-11-10) - MG01
-
memorandum-articles (2010-10-21) - MEM/ARTS
-
resolution (2010-10-21) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2010-08-16) - NEWINC