-
STAPLEHURST WINES LIMITED - Suite 4 Portfolio House, 3 Prince's Street, Dorchester, Dorset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07342699
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 4 Portfolio House
- 3 Prince's Street
- Dorchester
- Dorset
- DT1 1TP Suite 4 Portfolio House, 3 Prince's Street, Dorchester, Dorset, DT1 1TP UK
Management
- Geschäftsführung
- FROST, Susan Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.08.2010
- Alter der Firma 2010-08-11 13 Jahre
- SIC/NACE
- 47110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Susan Mary Frost
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-21
- Letzte Einreichung: 2021-09-07
-
STAPLEHURST WINES LIMITED Firmenbeschreibung
- STAPLEHURST WINES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07342699. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.08.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.08.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite 4 Portfolio House erreicht werden.
Jetzt sichern STAPLEHURST WINES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Staplehurst Wines Limited - Suite 4 Portfolio House, 3 Prince's Street, Dorchester, Dorset, Grossbritannien
- 2010-08-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STAPLEHURST WINES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-28) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-21) - CS01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-10-08) - 600
-
resolution (2021-10-08) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-10-08) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-10-08) - AD01
-
liquidation-disclaimer-notice (2021-10-28) - NDISC
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-24) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-08-21) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-15) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-31) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company (2017-03-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-08) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-04) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-11) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2012-12-11) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-14) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-12-12) - DISS40
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-28) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-12) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-10-12) - MG01
-
incorporation-company (2010-08-11) - NEWINC