-
SUBLIME CATERING LTD - 189 Harley Shute Road, St Leonards On Sea, East Sussex, TN38 9JJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07340408
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 189 Harley Shute Road
- St Leonards On Sea
- East Sussex
- TN38 9JJ
- United Kingdom 189 Harley Shute Road, St Leonards On Sea, East Sussex, TN38 9JJ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- KILIKITA, Toni-Louise
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.08.2010
- Alter der Firma 2010-08-09 13 Jahre
- SIC/NACE
- 56210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Toni-Louise Kilikita
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-07-31
- Letzte Einreichung: 2023-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-23
- Letzte Einreichung: 2023-08-09
-
SUBLIME CATERING LTD Firmenbeschreibung
- SUBLIME CATERING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07340408. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.08.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56210" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 189 Harley Shute Road erreicht werden.
Jetzt sichern SUBLIME CATERING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sublime Catering Ltd - 189 Harley Shute Road, St Leonards On Sea, East Sussex, TN38 9JJ, Grossbritannien
- 2010-08-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SUBLIME CATERING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-09-28) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-20) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-26) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-11-03) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-18) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-11-19) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-19) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-17) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-06-13) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-05-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-05-23) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-03-20) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-19) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-01-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-notice-compulsary (2011-12-06) - GAZ1
-
termination-secretary-company-with-name (2011-09-14) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-08-09) - NEWINC