-
GSAS (SHELF CO) LIMITED - Timber Terminal, Normandy Way, Goole, East Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07320583
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Timber Terminal
- Normandy Way
- Goole
- East Yorkshire
- DN14 5SP
- England Timber Terminal, Normandy Way, Goole, East Yorkshire, DN14 5SP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WAUD, Peter John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2010
- Gelöscht am:
- 2020-12-08
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Global Shipping Services Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- GLOBAL SHIPPING AUTOMOTIVE SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
-
GSAS (SHELF CO) LIMITED Firmenbeschreibung
- GSAS (SHELF CO) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07320583. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.07.2010 registriert. GSAS (SHELF CO) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GLOBAL SHIPPING AUTOMOTIVE SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Timber Terminal erreicht werden.
Jetzt sichern GSAS (SHELF CO) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gsas (Shelf Co) Limited - Timber Terminal, Normandy Way, Goole, East Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GSAS (SHELF CO) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-12-08) - GAZ2(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-28) - CS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-09-22) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-09-14) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-15) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-15) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-07) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-07) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-10-07) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-07) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-23) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-07-23) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2014-07-23) - CONNOT
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-07-09) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-01-28) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-24) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2013-11-15) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-10-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2013-11-27) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-11-18) - MR04
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2012-09-07) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date (2012-08-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type- (2012-04-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-03-27) - AA01
-
legacy (2012-01-20) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-10-11) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-07-20) - NEWINC