-
OVEN WIZARDS FRANCHISING LIMITED - 11 Dawes Close, Southrop, Lechlade, Gloucestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07319998
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Dawes Close
- Southrop
- Lechlade
- Gloucestershire
- GL7 3PR
- United Kingdom 11 Dawes Close, Southrop, Lechlade, Gloucestershire, GL7 3PR, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ABBOTT, Carol Vivienne May
- ABBOTT, Mark Jeffrey
- GRAHAM, Claire Elizabeth
- GRAHAM, John Jeffrey
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-20 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Jeffrey Graham
- Mr Mark Abbott
- Mr Mark Abbott
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-04-30
- Letzte Einreichung: 2023-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-14
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
-
OVEN WIZARDS FRANCHISING LIMITED Firmenbeschreibung
- OVEN WIZARDS FRANCHISING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07319998. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 11 Dawes Close erreicht werden.
Jetzt sichern OVEN WIZARDS FRANCHISING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Oven Wizards Franchising Limited - 11 Dawes Close, Southrop, Lechlade, Gloucestershire, Grossbritannien
- 2010-07-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OVEN WIZARDS FRANCHISING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-06-21) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-21) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-07) - AA
-
capital-allotment-shares (2021-07-27) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-28) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-08-07) - SH08
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-15) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-09-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-20) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-07-15) - SH08
-
resolution (2020-07-15) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-25) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-09) - AP01
-
incorporation-company (2010-07-20) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name (2010-08-09) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2010-08-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-08-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-08-12) - TM02