-
MONTPELLIER RESOURCING LTD - Suite L Radford Business Centre, Radford Way, Billericay, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07310464
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite L Radford Business Centre
- Radford Way
- Billericay
- Essex
- CM12 0BZ
- United Kingdom Suite L Radford Business Centre, Radford Way, Billericay, Essex, CM12 0BZ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BARNABAS, Myles Gordon
- BARNABAS, Tracy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-09 13 Jahre
- SIC/NACE
- 78300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Myles Barnabas
- Mr Myles Gordon Barnabas
- Mrs Tracy Jean Barnabas
- Tracy Barnabas
- Mrs Tracy Barnabas
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-07-30
- Letzte Einreichung: 2018-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-07-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-23
- Letzte Einreichung: 2020-07-09
-
MONTPELLIER RESOURCING LTD Firmenbeschreibung
- MONTPELLIER RESOURCING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07310464. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78300" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.07.2013.Die Firma kann schriftlich über Suite L Radford Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern MONTPELLIER RESOURCING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Montpellier Resourcing Ltd - Suite L Radford Business Centre, Radford Way, Billericay, Essex, Grossbritannien
- 2010-07-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MONTPELLIER RESOURCING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-13) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-07-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-31) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-04-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-11) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-11) - PSC04
-
capital-allotment-shares (2018-04-16) - SH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-16) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-16) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-09) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-25) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-07-30) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-03) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-06-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-25) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-09-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-08-01) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-26) - AD01
-
incorporation-company (2010-07-09) - NEWINC