-
SMART INNOVATIONS GRID LIMITED - C/O Poppleton & Appleby, 30 St Paul's Square, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07309284
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Poppleton & Appleby
- 30 St Paul's Square
- Birmingham
- West Midlands
- B3 1QZ
- England C/O Poppleton & Appleby, 30 St Paul's Square, Birmingham, West Midlands, B3 1QZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BASS, Graham John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.07.2010
- Gelöscht am:
- 2020-08-01
- SIC/NACE
- 27900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James Richard Allen
- Green Energy Networks Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-18
- Letzte Einreichung: 2018-08-04
-
SMART INNOVATIONS GRID LIMITED Firmenbeschreibung
- SMART INNOVATIONS GRID LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07309284. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.07.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "27900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Poppleton & Appleby erreicht werden.
Jetzt sichern SMART INNOVATIONS GRID LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smart Innovations Grid Limited - C/O Poppleton & Appleby, 30 St Paul's Square, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMART INNOVATIONS GRID LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2020-05-01) - AM23
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-10) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-11) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-10) - AD01
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-12-09) - AM10
-
liquidation-in-administration-proposals (2019-07-10) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2019-07-18) - AM06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-27) - TM01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2019-05-28) - AM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-20) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-20) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-08) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-07-08) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-25) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-08) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-03-01) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-27) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-19) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-17) - CH01
-
legacy (2012-09-18) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-07-14) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-12) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-03-08) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-07-09) - NEWINC