-
STEPHENSON COATES LIMITED - West 2, Asama Court, Newcastle Business Park, Newcastle Upon Tyne, NE4 7YD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07305752
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- West 2, Asama Court
- Newcastle Business Park
- Newcastle Upon Tyne
- NE4 7YD West 2, Asama Court, Newcastle Business Park, Newcastle Upon Tyne, NE4 7YD UK
Management
- Geschäftsführung
- DOCHERTY, Paul William
- OSWALD, John Howard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.07.2010
- Alter der Firma 2010-07-06 13 Jahre
- SIC/NACE
- 69201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr John Howard Oswald
- Mr Paul William Docherty
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- MANAGING ACCOUNTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-20
- Letzte Einreichung: 2023-07-06
-
STEPHENSON COATES LIMITED Firmenbeschreibung
- STEPHENSON COATES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07305752. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.07.2010 registriert. STEPHENSON COATES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MANAGING ACCOUNTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.07.2012.Die Firma kann schriftlich über West 2, Asama Court erreicht werden.
Jetzt sichern STEPHENSON COATES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stephenson Coates Limited - West 2, Asama Court, Newcastle Business Park, Newcastle Upon Tyne, NE4 7YD, Grossbritannien
- 2010-07-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STEPHENSON COATES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-03-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-01) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-01) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-07-12) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2017-06-19) - SH06
-
resolution (2017-06-19) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
memorandum-articles (2016-04-06) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
certificate-change-of-name-company (2012-04-02) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-02) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-10-05) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-10-05) - SH01
-
legacy (2012-11-27) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-07-18) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-07-06) - NEWINC