-
GREENER FOR LIFE ENERGY LIMITED - Balliol House, Southernhay Gardens, Exeter, EX1 1NP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07299915
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Balliol House
- Southernhay Gardens
- Exeter
- EX1 1NP Balliol House, Southernhay Gardens, Exeter, EX1 1NP UK
Management
- Geschäftsführung
- BALDWIN, Timothy John
- COLE, Stuart Michael
- REED, Winston Kenneth
- VALENTINE, Duncan Norman
- VOSS, Mark Stewart
- Prokuristen
- OPENSHAW, Nicholas Henry Folliott
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.06.2010
- Gelöscht am:
- 2021-11-12
- SIC/NACE
- 01630
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Winston Kenneth Reed
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-12-31
- Letzte Einreichung: 2016-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-07-14
- Letzte Einreichung: 2017-06-30
-
GREENER FOR LIFE ENERGY LIMITED Firmenbeschreibung
- GREENER FOR LIFE ENERGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07299915. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 30.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01630" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Balliol House erreicht werden.
Jetzt sichern GREENER FOR LIFE ENERGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Greener For Life Energy Limited - Balliol House, Southernhay Gardens, Exeter, EX1 1NP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREENER FOR LIFE ENERGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-03-24) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-03-24) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-11-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-09-20) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-15) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-09-14) - 600
-
resolution (2017-09-14) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-06-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-11) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-03-09) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2016-03-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-12-22) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-12-22) - SH08
-
resolution (2014-12-22) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-05) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2013-05-21) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-05-21) - AP03
-
capital-allotment-shares (2013-05-21) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-05) - AP01
-
resolution (2013-05-31) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-19) - AR01
-
resolution (2013-08-16) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-06) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-01-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-06-30) - NEWINC