-
KIMCHIKUNN LTD - 4 Beaconsfield Road, St Albans, Hertfordshire, AL1 3RD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07294152
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Beaconsfield Road
- St Albans
- Hertfordshire
- AL1 3RD 4 Beaconsfield Road, St Albans, Hertfordshire, AL1 3RD UK
Management
- Geschäftsführung
- KUNN, Kim-Chi Stephanie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-24 14 Jahre
- SIC/NACE
- 56290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Kim-Chi Stephanie Kunn
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-06-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-18
- Letzte Einreichung: 2019-05-04
-
KIMCHIKUNN LTD Firmenbeschreibung
- KIMCHIKUNN LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07294152. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 24.06.2013.Die Firma kann schriftlich über 4 Beaconsfield Road erreicht werden.
Jetzt sichern KIMCHIKUNN LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kimchikunn Ltd - 4 Beaconsfield Road, St Albans, Hertfordshire, AL1 3RD, Grossbritannien
- 2010-06-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KIMCHIKUNN LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-09-09) - LIQ14
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-08) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-01-07) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-01-07) - 600
-
resolution (2020-01-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-disclaimer-notice (2020-01-27) - NDISC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-29) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-26) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-25) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-04) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-07) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-09-16) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-14) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-14) - PSC01
-
gazette-notice-compulsory (2017-09-12) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-29) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-15) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-10-23) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-10-22) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-03-16) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-06-27) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-28) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-05) - AR01
-
legacy (2011-03-02) - MG01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-07-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-06-29) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-06-24) - TM01
-
incorporation-company (2010-06-24) - NEWINC