-
GOTIM 7 LIMITED - Mill House Lugg Bridge Mill, Worcester Road, Hereford, HR1 3NA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07285535
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Mill House Lugg Bridge Mill
- Worcester Road
- Hereford
- HR1 3NA Mill House Lugg Bridge Mill, Worcester Road, Hereford, HR1 3NA UK
Management
- Geschäftsführung
- BLANDFORD, Mark Robert
- EYNON, Philip John
- SAVORY, Alan
- Prokuristen
- SAVORY, Samantha Lee
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Gotim, Flats And Buildings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- Gotim 7 Limited
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-25
- Letzte Einreichung: 2023-10-11
-
GOTIM 7 LIMITED Firmenbeschreibung
- GOTIM 7 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07285535. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Mill House Lugg Bridge Mill erreicht werden.
Jetzt sichern GOTIM 7 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gotim 7 Limited - Mill House Lugg Bridge Mill, Worcester Road, Hereford, HR1 3NA, Grossbritannien
- 2010-06-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GOTIM 7 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-10-18) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-03-24) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-03-24) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2021-03-24) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-10-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-10-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-30) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-30) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-18) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-20) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-11-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-11-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-26) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-12-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-11-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-10-26) - AA
-
resolution (2012-02-13) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-02-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-01) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-23) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-10-22) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-10-22) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-12-09) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-01-19) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-23) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-06-22) - AA01
-
incorporation-company (2010-06-15) - NEWINC