-
MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED - Suite G2 Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07285271
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite G2 Montpellier House
- Montpellier Drive
- Cheltenham
- GL50 1TY Suite G2 Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TY UK
Management
- Geschäftsführung
- BEACH, George Richard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.06.2010
- Gelöscht am:
- 2023-12-02
- SIC/NACE
- 01240
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr George Richard Beach
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- MUDWALLS FARM LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-28
- Letzte Einreichung: 2021-06-14
-
MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED Firmenbeschreibung
- MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07285271. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.06.2010 registriert. MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MUDWALLS FARM LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01240" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite G2 Montpellier House erreicht werden.
Jetzt sichern MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mudwalls Farm (Dunnington) Limited - Suite G2 Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-12-02) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-09-02) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-09-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-09) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-11) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-19) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-13) - TM01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-08-05) - LIQ02
-
resolution (2021-08-05) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-05) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-03) - CS01
-
resolution (2020-05-30) - RESOLUTIONS
-
resolution (2020-05-29) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-29) - AP01
-
change-of-name-notice (2020-07-16) - CONNOT
-
resolution (2020-07-16) - RESOLUTIONS
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2020-08-21) - MR05
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-09-23) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-14) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-14) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-03-01) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-29) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-12) - MR01
-
capital-allotment-shares (2018-06-11) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-25) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-18) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-26) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-02) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-26) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-06-26) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-09-27) - TM01
-
incorporation-company (2010-06-15) - NEWINC