• UK
  • MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED - Suite G2 Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TY, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
07285271
Firmenstatus
GELÖSCHT
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Suite G2 Montpellier House
Montpellier Drive
Cheltenham
GL50 1TY
Suite G2 Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TY UK

Management

Geschäftsführung
BEACH, George Richard

Firmendetails

Geschäftszweig
ltd
Gründungsdatum
15.06.2010
Gelöscht am:
2023-12-02
SIC/NACE
01240

Eigentumsverhältnisse

Beneficial Owners
Mr George Richard Beach
-

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
Dissolved
Ehemalige Namen
MUDWALLS FARM LIMITED
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit: 2022-01-31
Letzte Einreichung: 2020-04-30
lezte Bilanzhinterlegung
2012-06-15
Jahresmeldung
Fälligkeit: 2022-06-28
Letzte Einreichung: 2021-06-14

MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED Firmenbeschreibung

MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07285271. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.06.2010 registriert. MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MUDWALLS FARM LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01240" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite G2 Montpellier House erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: Mudwalls Farm (Dunnington) Limited - Suite G2 Montpellier House, Montpellier Drive, Cheltenham, GL50 1TY, Grossbritannien

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MUDWALLS FARM (DUNNINGTON) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • gazette-dissolved-liquidation (2023-12-02) - GAZ2

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-09-02) - LIQ14

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-09-20) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-09) - MR04

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-18) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-11) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-08) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-19) - AA

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-13) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-08-05) - LIQ02

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2021-08-05) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-05) - 600

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-16) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-01-29) - AA

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2020-07-03) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2020-05-30) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2020-05-29) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-29) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • change-of-name-notice (2020-07-16) - CONNOT

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2020-07-16) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2020-08-21) - MR05

    In den Warenkorb
     
  • capital-allotment-shares (2019-09-23) - SH01

    In den Warenkorb
     
  • cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-14) - PSC07

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2019-06-14) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • capital-allotment-shares (2019-03-01) - SH01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-01-29) - AA

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-29) - MR04

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2018-06-22) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-30) - AA

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-12) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • capital-allotment-shares (2018-06-11) - SH01

    In den Warenkorb
     
  • notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2017-07-07) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-25) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-18) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-11) - AA

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-26) - AA

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-10) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-10) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-02) - AA

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-02) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-26) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-23) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-28) - AA

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-12) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-30) - AA

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-26) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-06-26) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-27) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name (2010-09-28) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name (2010-09-27) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2010-06-15) - NEWINC

    In den Warenkorb
     
expand_less