-
CASARTELLI PLANT HIRE LIMITED - 18 Hanover Street, Liverpool, Merseyside, L1 4AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07270560
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 18 Hanover Street
- Liverpool
- Merseyside
- L1 4AA 18 Hanover Street, Liverpool, Merseyside, L1 4AA UK
Management
- Geschäftsführung
- GILLBANKS, Cecilia Anne
- GILLBANKS, Daniel Alexander
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.06.2010
- Gelöscht am:
- 2023-11-21
- SIC/NACE
- 77320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Cecilia Ann Gillbanks
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- PILING PLANT HIRE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-21
- Letzte Einreichung: 2020-07-07
-
CASARTELLI PLANT HIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- CASARTELLI PLANT HIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07270560. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 01.06.2010 registriert. CASARTELLI PLANT HIRE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PILING PLANT HIRE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77320" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 18 Hanover Street erreicht werden.
Jetzt sichern CASARTELLI PLANT HIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Casartelli Plant Hire Limited - 18 Hanover Street, Liverpool, Merseyside, L1 4AA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CASARTELLI PLANT HIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-08-17) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-10-02) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-01) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-09-25) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-11-04) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2015-11-03) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-15) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-07-10) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-09) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-09) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-10-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-30) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-04-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-13) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-01-27) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-07) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-07-07) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2011-07-07) - CERTNM
-
certificate-change-of-name-company (2011-06-30) - CERTNM
-
certificate-change-of-name-company (2011-06-14) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-06-01) - NEWINC