-
HOTEL 27 LIMITED - 198 West End Lane, London, NW6 1SG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07259930
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 198 West End Lane
- London
- NW6 1SG 198 West End Lane, London, NW6 1SG UK
Management
- Geschäftsführung
- LAWEE, Aaron Arik
- LAWEE, Robert William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-20 14 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Aaron Arik Lawee
- Mr Robert William Lawee
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-02-29
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-23
- Letzte Einreichung: 2023-05-09
-
HOTEL 27 LIMITED Firmenbeschreibung
- HOTEL 27 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07259930. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 198 West End Lane erreicht werden.
Jetzt sichern HOTEL 27 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hotel 27 Limited - 198 West End Lane, London, NW6 1SG, Grossbritannien
- 2010-05-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HOTEL 27 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-23) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-07-18) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-07-18) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2023-09-05) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-09-21) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-08-06) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-05) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-08-05) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-27) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-09) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-09) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-09) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-28) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-20) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-12) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-01) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-05-20) - NEWINC
-
legacy (2010-12-04) - MG01
-
capital-allotment-shares (2010-06-08) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2010-05-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-08) - AP01