-
COOPER INDUSTRIES UK SUBCO LIMITED - 6, Jephson Court, Tancred Close, Leamington Spa, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07259915
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6
- Jephson Court
- Tancred Close
- Leamington Spa
- Warwickshire
- CV31 3RZ
- England 6, Jephson Court, Tancred Close, Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOWES, Richard Paul
- JACKSON, Andrew
- MULLIN, Martin Gerard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.05.2010
- Gelöscht am:
- 2020-12-22
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Cooper Industries Llc
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-03
- Letzte Einreichung: 2020-05-20
-
COOPER INDUSTRIES UK SUBCO LIMITED Firmenbeschreibung
- COOPER INDUSTRIES UK SUBCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07259915. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 6 erreicht werden.
Jetzt sichern COOPER INDUSTRIES UK SUBCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cooper Industries Uk Subco Limited - 6, Jephson Court, Tancred Close, Leamington Spa, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COOPER INDUSTRIES UK SUBCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-12-22) - GAZ2(A)
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-21) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-21) - CS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-10-06) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-06-10) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-09-24) - DS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-10) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-24) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-05) - CS01
-
legacy (2018-07-13) - CAP-SS
-
resolution (2018-07-13) - RESOLUTIONS
-
legacy (2018-07-13) - SH20
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-08-17) - AA
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-09-07) - SH19
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-13) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-02-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-09) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-07-09) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-09-06) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-10-31) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-10-25) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2012-07-12) - AP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-11-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-05-20) - NEWINC
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-08-24) - CH01
-
capital-allotment-shares (2010-07-08) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-05-21) - AA01