-
QUATTRO FOODS LIMITED - 8 The Nelson Centre, Portfield Road, Portsmouth, PO3 5SF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07248943
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 The Nelson Centre
- Portfield Road
- Portsmouth
- PO3 5SF 8 The Nelson Centre, Portfield Road, Portsmouth, PO3 5SF UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWER, Samantha Claire
- BUTLER, Raymond
- SIMON, Robert Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-11 14 Jahre
- SIC/NACE
- 10890
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Samantha Claire Brower
- Mr Robert Andrew Simon
- Mr Harold Simon
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-25
- Letzte Einreichung: 2021-05-11
-
QUATTRO FOODS LIMITED Firmenbeschreibung
- QUATTRO FOODS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07248943. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10890" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 8 The Nelson Centre erreicht werden.
Jetzt sichern QUATTRO FOODS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Quattro Foods Limited - 8 The Nelson Centre, Portfield Road, Portsmouth, PO3 5SF, Grossbritannien
- 2010-05-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QUATTRO FOODS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-05-20) - PSC01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-11) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-31) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-19) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-22) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-09) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-30) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-11-30) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-10) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-18) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-02-27) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-21) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-09) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-03-03) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-25) - AR01
-
legacy (2011-01-04) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-09) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-12-08) - CH01
-
legacy (2011-08-09) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-07-20) - MG01
-
resolution (2010-07-07) - RESOLUTIONS
-
resolution (2010-06-24) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-24) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-06-24) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-24) - AD01
-
capital-allotment-shares (2010-06-24) - SH01
-
incorporation-company (2010-05-11) - NEWINC