-
HARRINGTON STARR LIMITED - 68 Upper Thames Street, Vintners Place, London, EC4V 3BJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07246003
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 68 Upper Thames Street
- Vintners Place
- London
- EC4V 3BJ
- England 68 Upper Thames Street, Vintners Place, London, EC4V 3BJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BABB, Toby Benjamin
- LESS, Daniel David
- LESS, Stephen Stuart Samuel
- Prokuristen
- BABB, Michele
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-06 14 Jahre
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Toby Benjamin Babb
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-29
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-12
- Letzte Einreichung: 2021-10-29
-
HARRINGTON STARR LIMITED Firmenbeschreibung
- HARRINGTON STARR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07246003. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 68 Upper Thames Street erreicht werden.
Jetzt sichern HARRINGTON STARR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Harrington Starr Limited - 68 Upper Thames Street, Vintners Place, London, EC4V 3BJ, Grossbritannien
- 2010-05-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HARRINGTON STARR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-02) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-09-29) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-25) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-13) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-24) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-30) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-24) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-23) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-20) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-11) - GAZ1
-
resolution (2018-09-06) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-14) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-15) - DISS40
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-11-29) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-11-28) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-03) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-03) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-06-03) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-24) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-05-22) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-13) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-21) - MR01
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2015-03-12) - MR05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-07-12) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-30) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-notice-compulsary (2012-05-08) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-11) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-05-12) - DISS40
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-08-17) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-10) - AP01
-
capital-allotment-shares (2010-05-10) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2010-05-06) - TM01
-
incorporation-company (2010-05-06) - NEWINC