-
DB PACKING HOLDINGS LIMITED - Stone House, 56 North Street, Goole, East Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07240528
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Stone House
- 56 North Street
- Goole
- East Yorkshire
- DN14 5RA
- England Stone House, 56 North Street, Goole, East Yorkshire, DN14 5RA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AAROSIN, Peter
- KROLL, Jan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-30 14 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Danbrit Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SJP67 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-14
- Letzte Einreichung: 2021-04-30
-
DB PACKING HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- DB PACKING HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07240528. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.04.2010 registriert. DB PACKING HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SJP67 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Stone House erreicht werden.
Jetzt sichern DB PACKING HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Db Packing Holdings Limited - Stone House, 56 North Street, Goole, East Yorkshire, Grossbritannien
- 2010-04-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DB PACKING HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-27) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-27) - PSC05
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-03-21) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-02) - CS01
-
change-of-name-notice (2018-03-21) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-18) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-17) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-17) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-05-28) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-05-28) - AP03
-
capital-allotment-shares (2010-05-28) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-06-11) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-05-28) - TM02
-
resolution (2010-05-28) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2010-05-28) - TM01
-
incorporation-company (2010-04-30) - NEWINC