-
NOBLE CUSTOM LIMITED - Custom House Hillside Farm, Rempstone Road, Wymeswold, Leicestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07222803
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Custom House Hillside Farm
- Rempstone Road
- Wymeswold
- Leicestershire
- LE12 6UE
- United Kingdom Custom House Hillside Farm, Rempstone Road, Wymeswold, Leicestershire, LE12 6UE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- NOBLE, Samuel Patrick
- NOBLE, William
- PARRY-JONES, Miles
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-14 14 Jahre
- SIC/NACE
- 47640
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Miles Parry-Jones
- Mr William Noble
- -
- Mrs Janet Noble
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-17
- Letzte Einreichung: 2022-12-03
-
NOBLE CUSTOM LIMITED Firmenbeschreibung
- NOBLE CUSTOM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07222803. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47640" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Custom House Hillside Farm erreicht werden.
Jetzt sichern NOBLE CUSTOM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Noble Custom Limited - Custom House Hillside Farm, Rempstone Road, Wymeswold, Leicestershire, Grossbritannien
- 2010-04-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NOBLE CUSTOM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-18) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-04-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-06-02) - PSC07
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-24) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-25) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-24) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-23) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-23) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-23) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-23) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-14) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-14) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-04) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-07-03) - SH01
-
resolution (2017-07-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-21) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-05) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-15) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-05-06) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-04-14) - NEWINC