-
LIFE SCIENCE SUPPLIES LTD - 3b Humphrys Road, Woodside Estate, Dunstable, LU5 4TP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07215911
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3b Humphrys Road
- Woodside Estate
- Dunstable
- LU5 4TP
- England 3b Humphrys Road, Woodside Estate, Dunstable, LU5 4TP, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-07 14 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Robert Gilson
- Mr Nicolas Paris
- Mr Robert Gilson
- Mr Nicolas Paris
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-21
- Letzte Einreichung: 2021-04-07
-
LIFE SCIENCE SUPPLIES LTD Firmenbeschreibung
- LIFE SCIENCE SUPPLIES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07215911. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3B Humphrys Road erreicht werden.
Jetzt sichern LIFE SCIENCE SUPPLIES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Life Science Supplies Ltd - 3b Humphrys Road, Woodside Estate, Dunstable, LU5 4TP, Grossbritannien
- 2010-04-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LIFE SCIENCE SUPPLIES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-11-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-07) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-10-13) - TM02
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-08-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-15) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-06-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-08-25) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-12-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-11-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-01-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-09-18) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-07-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-26) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-11-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-02-02) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2011-02-11) - SH01
-
legacy (2011-03-01) - MG02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-03-09) - AP01
-
memorandum-articles (2011-04-07) - MEM/ARTS
-
capital-allotment-shares (2011-03-31) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-08) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-09-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-10-11) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-04-07) - NEWINC
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-10-19) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2010-10-19) - TM02
-
legacy (2010-07-16) - MG01
-
capital-allotment-shares (2010-05-13) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2010-05-13) - TM01