-
THE SAMUELSON CONSTRUCTION GROUP LIMITED - 1 Kings Avenue, London, N21 3NA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07208719
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Kings Avenue
- London
- N21 3NA 1 Kings Avenue, London, N21 3NA UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- CAA REGISTRARS LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-30 14 Jahre
- SIC/NACE
- 41201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Berthold Wylie Samuelson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-29
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-13
- Letzte Einreichung: 2019-03-30
-
THE SAMUELSON CONSTRUCTION GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- THE SAMUELSON CONSTRUCTION GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07208719. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41201" registriert. und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 1 Kings Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern THE SAMUELSON CONSTRUCTION GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Samuelson Construction Group Limited - 1 Kings Avenue, London, N21 3NA, Grossbritannien
- 2010-03-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE SAMUELSON CONSTRUCTION GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-02-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-02-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-02-18) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-10-13) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2022-10-13) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-03-03) - LIQ03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-01-31) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-02) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-12-31) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-12-31) - 600
-
resolution (2019-12-31) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-03) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-13) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-08) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-14) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-04-13) - TM02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-04-13) - AP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-13) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-11-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-16) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-05-16) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-05-16) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-03-30) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-04-20) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2010-04-20) - AP04