-
REGULUS PROPERTIES LIMITED - 1 Kings Avenue, London, N21 3NA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07208407
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Kings Avenue
- London
- N21 3NA 1 Kings Avenue, London, N21 3NA UK
Management
- Geschäftsführung
- STAFFORD, Lori
- STAFFORD, Mark Andrew
- Prokuristen
- STAFFORD, Lorraine
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.03.2010
- Gelöscht am:
- 2021-03-30
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Lorraine Stafford
- Mr Mark Andrew Stafford
- Mrs Lorraine Stafford
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-05-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-13
- Letzte Einreichung: 2019-03-30
-
REGULUS PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- REGULUS PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07208407. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 30.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Kings Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern REGULUS PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Regulus Properties Limited - 1 Kings Avenue, London, N21 3NA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REGULUS PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-03-30) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-30) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-02) - AD01
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-12-30) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-10-31) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-10-31) - 600
-
resolution (2019-10-31) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-08-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-09) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-26) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2015-12-08) - RP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-16) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-allotment-shares (2010-06-23) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-04-23) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-04-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-04-22) - TM01
-
incorporation-company (2010-03-30) - NEWINC