-
TBSM LIMITED - Silbury Court, 420 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes, MK9 2AF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07196025
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Silbury Court
- 420 Silbury Boulevard
- Central Milton Keynes
- MK9 2AF
- England Silbury Court, 420 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes, MK9 2AF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SPATICCHIA, Jan Franco
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-19 14 Jahre
- SIC/NACE
- 93130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jan Franco Spaticchia
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-13
- Letzte Einreichung: 2020-07-30
-
TBSM LIMITED Firmenbeschreibung
- TBSM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07196025. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93130" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.03.2012.Die Firma kann schriftlich über Silbury Court erreicht werden.
Jetzt sichern TBSM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tbsm Limited - Silbury Court, 420 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes, MK9 2AF, Grossbritannien
- 2010-03-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TBSM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-11-06) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-10-19) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-06) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-19) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-06) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-06) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-08-06) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-01) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2019-06-11) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-27) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-27) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-06-27) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC05
-
change-corporate-director-company-with-change-date (2019-11-01) - CH02
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-01) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-10-17) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-04) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-04) - PSC05
-
change-corporate-director-company-with-change-date (2018-04-04) - CH02
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-08) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-10) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-10) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2017-02-10) - AP02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-12-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-12-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-15) - AD01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2013-01-02) - AAMD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-04-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-04-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-03-19) - NEWINC