-
UNIWARM LIMITED - 6 St John's Close, Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07194982
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6 St John's Close
- Bovey Tracey
- Newton Abbot
- Devon
- TQ13 9BU 6 St John's Close, Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, TQ13 9BU UK
Management
- Geschäftsführung
- O'GRADY, Patrick James
- Prokuristen
- KNAPTON, Anthony John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-18 14 Jahre
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Patrick James O'Grady
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-20
- Letzte Einreichung: 2023-03-06
-
UNIWARM LIMITED Firmenbeschreibung
- UNIWARM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07194982. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 6 St John's Close erreicht werden.
Jetzt sichern UNIWARM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Uniwarm Limited - 6 St John's Close, Bovey Tracey, Newton Abbot, Devon, Grossbritannien
- 2010-03-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UNIWARM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-05-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-25) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-27) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-19) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-08) - MR01
-
resolution (2015-05-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-04-17) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-12-03) - RESOLUTIONS
-
resolution (2014-08-01) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-07-14) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-19) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-03-05) - TM01
-
capital-allotment-shares (2014-11-21) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-12-31) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-12-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-06-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-05-10) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-02-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-02-02) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2012-02-02) - MEM/ARTS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-12-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-05-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-11-24) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2011-11-22) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-24) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-11) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-04-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-03-18) - NEWINC