-
ASCROFT WHITESIDE LIMITED - 269 Church Street, Blackpool, Lancashire, FY1 3PB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07194642
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 269 Church Street
- Blackpool
- Lancashire
- FY1 3PB 269 Church Street, Blackpool, Lancashire, FY1 3PB UK
Management
- Geschäftsführung
- BOOTH, Graeme Timothy
- REID, Fiona
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-18 14 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Fiona Reid
- Ms Fiona Reid
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-04-01
- Letzte Einreichung: 2017-03-18
-
ASCROFT WHITESIDE LIMITED Firmenbeschreibung
- ASCROFT WHITESIDE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07194642. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 269 Church Street erreicht werden.
Jetzt sichern ASCROFT WHITESIDE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ascroft Whiteside Limited - 269 Church Street, Blackpool, Lancashire, FY1 3PB, Grossbritannien
- 2010-03-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ASCROFT WHITESIDE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-10-27) - GAZ1
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-02-25) - AM10
-
liquidation-in-administration-end-of-administration (2020-02-14) - AM21
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-03-29) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2019-02-01) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-09-24) - AM10
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-07) - AD01
-
liquidation-in-administration-progress-report (2018-09-27) - AM10
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2018-04-18) - AM02
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2018-04-13) - AM02
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2018-03-28) - AM06
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-03-07) - AM03
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-02-28) - AM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-11) - CS01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2017-04-11) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2017-03-22) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2017-03-22) - AD02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-14) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-21) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-04-23) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-15) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-28) - AR01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-01-15) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-01-15) - SH08
-
resolution (2014-01-15) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-07-12) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-23) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-03-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-03-18) - NEWINC