-
FOLDE DESIGN LIMITED - CURRIE YOUNG LIMITED, Alexander House Waters Edge Business Park, Campbell Road, Stoke-On-Trent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07187621
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- CURRIE YOUNG LIMITED
- Alexander House Waters Edge Business Park
- Campbell Road
- Stoke-On-Trent
- Staffordshire
- ST4 4DB CURRIE YOUNG LIMITED, Alexander House Waters Edge Business Park, Campbell Road, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST4 4DB UK
Management
- Geschäftsführung
- JUDE, Dominic Martin
- Prokuristen
- THRUSSELL, David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.03.2010
- Gelöscht am:
- 2021-01-23
- SIC/NACE
- 41100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-12-31
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-03-26
- Letzte Einreichung:
-
FOLDE DESIGN LIMITED Firmenbeschreibung
- FOLDE DESIGN LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07187621. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 12.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2013 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Currie Young Limited erreicht werden.
Jetzt sichern FOLDE DESIGN LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Folde Design Limited - CURRIE YOUNG LIMITED, Alexander House Waters Edge Business Park, Campbell Road, Stoke-On-Trent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FOLDE DESIGN LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-01-23) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-10-23) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-08) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-12-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-12-14) - LIQ03
-
liquidation-court-order-miscellaneous (2017-12-05) - LIQ MISC OC
-
liquidation-voluntary-cease-to-act-as-liquidator (2017-12-05) - 4.40
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-11-07) - 4.20
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-28) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-09) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-11-07) - 600
-
resolution (2016-11-07) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-24) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-09-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-01-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-04-04) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-04) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-01-28) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-04-26) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-03-12) - NEWINC
-
resolution (2010-08-09) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2010-08-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-03-18) - TM01