-
HOLYSPORT LS LIMITED - 4th Floor Hartwell House, 55-61 Victoria St, Bristol, BS1 6AD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07176889
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor Hartwell House
- 55-61 Victoria St
- Bristol
- BS1 6AD 4th Floor Hartwell House, 55-61 Victoria St, Bristol, BS1 6AD UK
Management
- Geschäftsführung
- WEINHOLD, Richard Olivier
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.03.2010
- Gelöscht am:
- 2020-12-18
- SIC/NACE
- 46420
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard Olivier Weinhold
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-03-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-17
- Letzte Einreichung: 2018-03-03
-
HOLYSPORT LS LIMITED Firmenbeschreibung
- HOLYSPORT LS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07176889. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 03.03.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46420" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.03.2014.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor Hartwell House erreicht werden.
Jetzt sichern HOLYSPORT LS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Holysport Ls Limited - 4th Floor Hartwell House, 55-61 Victoria St, Bristol, BS1 6AD, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HOLYSPORT LS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-12-18) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-09-18) - 600
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-09-18) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-08-21) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-19) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-08-16) - 600
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-08-01) - DISS16(SOAS)
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-06-08) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-21) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-17) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-05-23) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-22) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-04) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-04-19) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-22) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-19) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-26) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-26) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-22) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-05) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-06) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-31) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-13) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-24) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-06) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-02) - AA
-
legacy (2013-03-15) - MG02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-02) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-16) - AR01
-
legacy (2012-06-02) - MG01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-01-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-07-30) - MG01
-
incorporation-company (2010-03-03) - NEWINC