-
HENRY THOMAS HOMES LIMITED - Victory House Quayside, Chatham Maritime, Chatham, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07148150
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Victory House Quayside
- Chatham Maritime
- Chatham
- Kent
- ME4 4QU
- England Victory House Quayside, Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WINTERBOTHAM, David Mark
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.02.2010
- Gelöscht am:
- 2020-10-06
- SIC/NACE
- 41201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Mark Winterbotham
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- GML HOMES (SOUTH) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-02-07
- Letzte Einreichung: 2019-01-24
-
HENRY THOMAS HOMES LIMITED Firmenbeschreibung
- HENRY THOMAS HOMES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07148150. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.02.2010 registriert. HENRY THOMAS HOMES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GML HOMES (SOUTH) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41201" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Victory House Quayside erreicht werden.
Jetzt sichern HENRY THOMAS HOMES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Henry Thomas Homes Limited - Victory House Quayside, Chatham Maritime, Chatham, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HENRY THOMAS HOMES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-10-06) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-04-02) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-04-14) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-04-24) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-23) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-04-16) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-02-19) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-20) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-20) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-03-30) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-01) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-25) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-09) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-05-23) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-25) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-09-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-11-29) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-03-16) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2011-03-16) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-04-20) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2011-09-09) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2011-09-09) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-07-07) - MG01
-
legacy (2010-09-24) - MG01
-
incorporation-company (2010-02-05) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-02-17) - AA01
-
legacy (2010-06-08) - MG01