-
SOUTH LAKES VETERINARY CENTRE LIMITED - The Chocolate Factory Somerdale, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07147058
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chocolate Factory Somerdale
- Keynsham
- Bristol
- BS31 2AU
- England The Chocolate Factory Somerdale, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GILLINGS, Mark Andrew
- CHAPMAN, Donna Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2010
- Alter der Firma 2010-02-04 14 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Tracy Marion Joy Malham
- Independent Vetcare Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-02-18
- Letzte Einreichung: 2022-02-04
-
SOUTH LAKES VETERINARY CENTRE LIMITED Firmenbeschreibung
- SOUTH LAKES VETERINARY CENTRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07147058. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.02.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 18.04.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Chocolate Factory Somerdale erreicht werden.
Jetzt sichern SOUTH LAKES VETERINARY CENTRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: South Lakes Veterinary Centre Limited - The Chocolate Factory Somerdale, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Grossbritannien
- 2010-02-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOUTH LAKES VETERINARY CENTRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-18) - CS01
-
legacy (2021-06-23) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-06-23) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-06-23) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-06-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-10-25) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-02-18) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-18) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-18) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-23) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-18) - PSC02
-
resolution (2019-05-13) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-08-13) - AA01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-08-19) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-23) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-23) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-12-06) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-12-06) - AA01
-
legacy (2010-07-06) - MG01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-29) - CH01
-
incorporation-company (2010-02-04) - NEWINC