-
SMART PHONE TECHNOLOGIES LIMITED - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07141353
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2-3 Winckley Court Chapel Street
- Preston
- PR1 8BU 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU UK
Management
- Geschäftsführung
- MERTENS, John Charles
- MICAELO, Tiago Filipe
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.01.2010
- Gelöscht am:
- 2023-03-19
- SIC/NACE
- 33190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Bennett Ingram Harley Moss
- -
- -
- Mr Tiago Filipe Micaelo
- Mr John Charles Mertens
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-14
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
-
SMART PHONE TECHNOLOGIES LIMITED Firmenbeschreibung
- SMART PHONE TECHNOLOGIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07141353. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 31.01.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2-3 Winckley Court Chapel Street erreicht werden.
Jetzt sichern SMART PHONE TECHNOLOGIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smart Phone Technologies Limited - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMART PHONE TECHNOLOGIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-18) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-13) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-22) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-27) - TM01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-11-18) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-11-18) - 600
-
resolution (2021-11-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-12-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-02) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-07) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-07) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-07) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-07) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-07) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-02) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-06-25) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2013-06-17) - SH06
-
resolution (2013-06-17) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-07-12) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-09-06) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-10-26) - AA01
-
capital-allotment-shares (2010-03-17) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-03-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-02-08) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-02-08) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2010-02-01) - TM01
-
incorporation-company (2010-01-31) - NEWINC