-
OMNIVERSE VISION LIMITED - 1st Floor 21 Station Road, Watford, Herts, WD17 1AP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07128364
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor 21 Station Road
- Watford
- Herts
- WD17 1AP 1st Floor 21 Station Road, Watford, Herts, WD17 1AP UK
Management
- Geschäftsführung
- GAYDON, John Christian
- SHAW, Austin Matthew Frederick
- Prokuristen
- SHAW, Austin Matthew Frederick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.01.2010
- Alter der Firma 2010-01-18 14 Jahre
- SIC/NACE
- 59131
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-12-31
- Letzte Einreichung: 2013-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-02-01
- Letzte Einreichung:
-
OMNIVERSE VISION LIMITED Firmenbeschreibung
- OMNIVERSE VISION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07128364. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.01.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59131" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.01.2013.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor 21 Station Road erreicht werden.
Jetzt sichern OMNIVERSE VISION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Omniverse Vision Limited - 1st Floor 21 Station Road, Watford, Herts, WD17 1AP, Grossbritannien
- 2010-01-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OMNIVERSE VISION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-01-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-02-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-12-04) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-17) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-12-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-01-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-12-02) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-11-13) - RESOLUTIONS
-
liquidation-disclaimer-notice (2015-12-11) - F10.2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-16) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-11-13) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-11-13) - 600
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-09-26) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2015-09-08) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-10) - AA
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2014-03-19) - MR05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-23) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-20) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-10-02) - MG02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-13) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-09) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-03-21) - AA01
-
gazette-notice-compulsary (2011-05-17) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-01) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-06-04) - DISS40
-
capital-allotment-shares (2011-09-20) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-22) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-09-29) - SH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-09-29) - AP03
-
legacy (2011-11-23) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-01-18) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2010-10-25) - SH01