-
TEMPUS TAX LTD - Netley House Shere Road, Gomshall, Guildford, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07116519
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Netley House Shere Road
- Gomshall
- Guildford
- Surrey
- GU5 9QA Netley House Shere Road, Gomshall, Guildford, Surrey, GU5 9QA UK
Management
- Geschäftsführung
- NEWBOULD, John Francis
- SMITH, Stephen
- LARGE, Ruth Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.01.2010
- Alter der Firma 2010-01-05 14 Jahre
- SIC/NACE
- 69203
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Miss Amanda Steele
- Mr John Newbould
- -
- Mr John Newbould
- Mrs Ruth Elizabeth Large
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- S4 TAXATION SERVICES LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-17
-
TEMPUS TAX LTD Firmenbeschreibung
- TEMPUS TAX LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07116519. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.01.2010 registriert. TEMPUS TAX LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen S4 TAXATION SERVICES LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69203" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Netley House Shere Road erreicht werden.
Jetzt sichern TEMPUS TAX LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Tempus Tax Ltd - Netley House Shere Road, Gomshall, Guildford, Surrey, Grossbritannien
- 2010-01-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TEMPUS TAX LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-19) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-11-17) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-10-19) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-11-17) - PSC01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-06-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-18) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-01-17) - SH08
-
resolution (2020-01-13) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-18) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-23) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-11-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-04-03) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-01) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-03-08) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-06) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-06) - AD01
-
gazette-notice-compulsary (2014-02-04) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-04-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-01-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-26) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2012-08-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-02-17) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-01-05) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-02-12) - AA01
-
capital-allotment-shares (2010-01-29) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-01-22) - AP01